Aperçu avant impression Fermer

Affichage de 5157 résultats

Description archivistique
Gages de l'équipage de l'Azora
Pièce
Fait partie de Fonds Père Clarence d'Entremont
Document original, imprimé et complété à la plume. Document daté le 10 avril 1877. Le document est adressé au propriétaire de l'Azora. On retrouve une liste de noms de (l'équipage) avec des montants à coté de chaque nom. Le document port l'entête de James Butler & Co., de Halifax. 1998.3-f11
Pièce · 1824
Fait partie de Fonds Père Clarence d'Entremont
Document original provenant de Benoni d'Entremont et de sa famille. Déclaration de Benoni d'Entremont selon laquelle Thomas Owens lui a payé la totalité de ce qu'il lui devait pour un hypothèque datant du 24 mai 1793. Le document est signé par Benoni d'Entremont, Edward Hipson et Joseph Joshua d'Entremont (témoins) le 18 mars 1824. 1998.3-f11
Testament de Charles Muse
Pièce · 19?
Fait partie de Fonds Père Clarence d'Entremont
Document original provenant de Benoni d'Entremont et de sa famille. Homologation du testament de Charles Muise (sic) par le tribunal des successions, signé par Sam Sheldon Pool (Juge de successions) le 4 avril 1806. 1998.3-f11
Lettre de Mme Paul A. d'Entremont
Pièce
Fait partie de Fonds Père Clarence d'Entremont
Copie d'un document, rédirigé à la plume. Lettre datée le 14 décembre 1896 Le docment est une lettre écrite par Mme. Paul (Alexandre) d'Entremont (à Arthense à Vital) à M. Clément d'Entremont (à Jean à Hilaire). La Lettre est une lettre de chaîne en faveur du Père Ducheneseau. 1998.3-f11
Havre de Pubnico
Pièce
Fait partie de Fonds Père Clarence d'Entremont
Photographie d'une carte gra[joqie des terres entourant le havre de Pubnico montrant la réparation des terres entre les différents propriétaires. La date, le titre, l'échelle et la provenance du document no sont pas indiqués. 1998.3-f11
Pièce · 1919-1920
Item consists of a ledger recording registered letters mailed at, received for delivery at, or passing through the Jeddore Oyster Pond Post Office, Oyster Pond, Halifax County, Nova Scotia, from June 14, 1919 to August 11, 1920. 2009.039
Lapierre_John_int_Eaton_6808
Pièce · August 15, 1980
Fait partie de Lena Ferguson fonds
This audio file is an excerpt from an interview with John Lapierre of Grand Desert conducted in August of 1980 by Lena Ferguson and Rosemary Eaton. The audio clip features Mr. Lapierre discussing his experience working on the schooner, the Village Leaf, as a young boy of fourteen. They sailed from the Chezzetcook area to the fishing grounds off the Magdalen Islands. 2019.014
Monthly time book
Pièce · 1942-1943
Item consists of a monthly time book that records the names of men and hours worked on a project from September to December 1942. It includes the names of at least sixty men who were working shifts of usually ten hours each day from Monday to Saturday. The name of the foreman given is Garth M. L. Hosking and the name B.H. Mitchell on the cover indicates that he was likely the contractor. The book also records the use of B.H. Mitchell's horse and truck, Reg Day's horse, and another company's truck. Although the nature of the project is not described, the men were probably working on constructing large floating barges to be used as part of the war effort during World War II. The barges were constructed locally at Hartlin Settlement and then carried by tugboat to Halifax Harbour. The main timbers used were imported, but the decking came from local mills, including Byron Mitchell's. Also recorded in the book are shifts worked by Garth Hosking during May and June 1943. Accession number 2010.003.
John Hays land grant
Pièce · 1786
Item consists of a land grant for a one hundred acre parcel of land in Jeddore, Halifax County, Nova Scotia which was awarded to John Hays by the Crown. The grant is dated August-September 1786. Accession number 2010.016.